123rd Maine Legislature - Second Regular Sesson
Legislative Requests Accepted by the Legislative Council
TRANSPORTATION
LR: 2737
Sponsor: Representative Knight
An Act To Amend the Laws Pertaining to Road Associations
LR: 2738
Sponsor: Representative Miramant
An Act To Ban the Use of Liquid Calcium Chloride on Roads
LR: 2775
Sponsor: Representative Hinck
An Act To Conserve Gasoline and Preserve Clean Air
LR: 2816
Sponsor: Senator Marrache
Resolve, To Prevent the Closing of Store Road in Somerset County
LR: 2888
Sponsor: Senator Damon
An Act Regarding Axle Weight on Tri-axle Farm Trucks
LR: 2966
Sponsor: Representative Kaenrath
An Act To Increase the Time Period for Motor Vehicle Inspections to 2 Years
LR: 2970
Sponsor: Representative Browne
An Act To Designate Certain Rules of the Bureau of State Police as Major Substantive Rules
LR: 2978
Sponsor: Representative Wagner
Resolve, To Change the Name of the South Bridge between Lewiston and Auburn
LR: 3009
Sponsor: Representative Miramant
An Act To Ensure That the Requirement of Airport Manager Training Does Not Affect the Issuance of an 
Annual Registration Certificate until January 1, 2009
LR: 3210
Sponsor: Representative Marley
An Act To Implement the Recommendations of the Governor's Task Force on Passenger Rail Funding
LR: 3278
Sponsor: Representative Mills, J.
An Act To Allow Nondangerous Drivers To Obtain a Work-restricted License
LR: 3343
Sponsor: Representative Wheeler
An Act To Require a Hearing When a Fatality Results from a Motor Vehicle Accident
LR: 3360
Sponsor: Senator Mills, P.
An Act To Authorize the Department of Transportation To Recover for the Highway Fund Any Money 
Recovered from Those Responsible for Doing Damage to State Roads and Bridges
Page 20 of 23
 11/16/2007   9:30:21AM